space Studies
italian
english
space Sources Dates Indices Topics1 Topics2 Reference Texts


NAMESANDROLES


SURNAMESETC.


WordsinNAMESANDROLES


PLACES


WordsinPLACES


INSTITUTIONS


WordsinINSTITUTIONS


A-E


F-K


L-O


P-S

T-Z


OTHER

A1-150  151-300 A301-364 


Previous
Santa
Next
 

sorted
Document

sort
Date

sort
Summary

sort
Context of query
o0201080.009a 1421/2 gennaio 29 Letter to the Podestà of Carmignano instructing him to demand payment of the church of Santa Cristina and arrest the rector of Carmignano. chiesa di Santa Cristina di Carmignano
o0201080.010a 1421/2 gennaio 29 Concession of right of recourse to debtor for property gabelles and testaments. (quartiere) di Santa Croce
o0201080.015d 1421/2 marzo 11 Confirmation of release sentence concerning property owner enjoined to pay. quartiere di Santa Maria Novella
o0201080.018vc 1421/2 marzo 17 Cancellation of debt for property gabelle erroneously ascribed. quartiere di Santa Maria Novella
o0201080.018vd 1421/2 marzo 17 Deduction of account entry erroneously debited twice. quartiere di Santa Croce
o0201080.065f 1421/2 gennaio 26 Restitution of tax not owed on testament. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0201080.080f 1421/2 gennaio 28 Guaranty for debt for taxes on testaments. convento di Santa Maria del Carmine
o0201080.081vb 1421/2 marzo 9 Guaranty for debt of the baptismal parish of San Cresci a Macioli. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0201081.019d 1422 settembre 16 Term of payment for debt for property gabelle. cappella di Santa Margherita in Santa Maria d'Ambra
o0201081.019d 1422 settembre 16 Term of payment for debt for property gabelle. cappella di Santa Margherita in Santa Maria d'Ambra
o0201081.024c 1422 ottobre 6 Term of payment for property gabelle to the parish of Santa Maria a Moriano. popolo di Santa Maria a Moriano
o0201081.027ve 1422 novembre 6 Concession of right of recourse for property gabelle to debtor who is no longer the owner. quartiere di Santa Croce
o0201081.029b 1422 novembre 23 Cancellation of debts for property gabelles due to double registration. chiesa di Santa Maria a Bisticci
o0201081.029b 1422 novembre 23 Cancellation of debts for property gabelles due to double registration. chiesa di Santa Lucia a Bisticci
o0201081.029vb 1422 novembre 24 Term of payment for debt for property and milling gabelles. popolo di Santa Croce di Dicomano
o0201081.031c 1422 dicembre 2 Cancellation of debt for property gabelle registered twice; unfinished act. chiesa di Santa ... di Romena
o0201081.082vg 1422 settembre 17 Guaranty for unspecified debt of the church of Santa Margherita in Santa Maria d'Ambra. chiesa di Santa Margherita nella chiesa di Santa Maria d'Ambra
o0201081.082vg 1422 settembre 17 Guaranty for unspecified debt of the church of Santa Margherita in Santa Maria d'Ambra. chiesa di Santa Margherita nella chiesa di Santa Maria d'Ambra
o0201081.083vc 1422 ottobre 7 Guaranty for unspecified debt of the parish of Santa Maria di Moriano in the baptismal parish of the Incisa. popolo di Santa Maria a Moriano
o0201082.004vb 1422/3 febbraio 19 Cancellation of debt for forced loans already paid in the new gabelles. quartiere di Santa Croce
o0201082.005vf 1422/3 marzo 9 Term of payment to the hospital of Santa Maria del Pellegrinaggio and restitution of pawns. ospedale di Santa Maria del Pellegrinaggio
o0201082.007vb 1422/3 marzo 16 Concession of right of recourse to the parish of Santa Maria a Moriano. chiesa di Santa Maria a Moriano
o0201082.007vb 1422/3 marzo 16 Concession of right of recourse to the parish of Santa Maria a Moriano. popolo di Santa Maria a Moriano
o0201082.007ve 1422/3 marzo 22 Term of payment for forced loans with confirmation of surety. quartiere di Santa Croce
o0201082.020b 1423 giugno 9 Term of payment for debt for forced loans and release of the arrested debtor. quartiere di Santa Maria Novella
o0201082.021c 1423 giugno 18 Revocation of demand of payment on properties declared not taxable by the office of the comptrollers. quartiere di Santa Croce
o0201082.065b 1422/3 febbraio 5 Restitution of tax for testamentary inheritance paid twice. compagnia delle Laudi in Santa Maria Novella
o0201082.065b 1422/3 febbraio 5 Restitution of tax for testamentary inheritance paid twice. (quartiere di) Santa Maria Novella
o0201082.082b 1422/3 febbraio 5 Arrest for debt for forced loans and pardons. quartiere di Santa Croce
o0201082.082va 1422/3 marzo 3 Arrest for debt for forced loans. quartiere di Santa Maria Novella
o0201082.082vb 1422/3 marzo 3 Arrest for debts of forced loans and pardons of forced loans. quartiere di Santa Maria Novella
o0201082.088e 1422/3 marzo 10 Guaranty for debt of the hospital of Santa Maria del Pellegrinaggio. ospedale di Santa Maria del Pellegrinaggio
o0201082.088f 1422/3 marzo 11 Guaranty for debt guaranteed by tenant of debtor. quartiere di Santa Croce
o0201082.088vb 1422/3 marzo 22 Guaranty for debt for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0201082.089vh 1423 giugno 14 Guaranty for debt for property gabelle. quartiere di Santa Maria Novella
o0201082.089vi 1423 giugno 16 Guaranty for unspecified debt. quartiere di Santa Maria Novella
o0201083.003vb 1423 luglio 29 Term of payment and release of an arrested person. quartiere di Santa Maria Novella
o0201083.006vb 1423 settembre 11 Resolution in favor of the rector of Santa Maria sopra Porta: unfinished act. chiesa di Santa Maria sopra Porta
o0201083.008c 1423 ottobre 5 Term of payment for debt for forced loans and release of the arrested debtor following guaranty. quartiere di Santa Maria Novella
o0201083.011a 1423 novembre 18 Prohibition to demand payment on properties for dotal rights. piviere di Santa Maria Impruneta
o0201083.088c 1423 luglio 29 Guaranty for unspecified debt. quartiere di Santa Maria Novella
o0201083.089e 1423 ottobre 16 Guaranty for debt for property gabelle. quartiere di Santa Maria Novella
o0201083.089f 1423 ottobre 25 Guaranty for debt for forced loans. quartiere di Santa Maria Novella
o0201083.089g 1423 ottobre 30 Guaranty for unspecified debt of the Commune of Santa Croce Valdarno. Comune di Santa Croce Valdarno
o0201083.089vd 1423 novembre 15 Guaranty for debt for property gabelle. quartiere di Santa Maria Novella
o0201083.092c 1423 luglio 20 Arrest for unspecified debt. quartiere di Santa Maria Novella
o0201083.092vh 1423 ottobre 16 Term of payment and arrest for debt for property gabelle. quartiere di Santa Maria Novella
o0201083.092vi 1423 ottobre 23 Arrest for unspecified debt. quartiere di Santa Maria Novella
o0201083.092vl 1423 dicembre 3 Arrest for unspecified debt. quartiere di Santa Croce
o0201083.092vm 1423 dicembre 3 Arrest for debt for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0201084.002c 1423/4 gennaio 10 Term of payment with release of arrested person. quartiere di Santa Croce
o0201084.002d 1423/4 gennaio 10 Restitution of pawns to debtor registered in two account entries with cancellation of debt without expenses. quartiere di Santa Maria Novella
o0201084.002va 1423/4 gennaio 13 Letter to the Podestà of Prato with summons for debt for forced loans and restitution of pawns to holder of debtor's properties. quartiere di Santa Maria Novella
o0201084.003vb 1423/4 gennaio 27 Prohibition to demand payment from the hospital of Santa Maria Nuova, because it is a charitable institution, and to demand payment of, arrest and distrain its personnel. ospedale di Santa Maria Nuova
o0201084.004vb 1423/4 gennaio 27 Term of payment for debt for property gabelle to possessors of debtors' properties. quartiere di Santa Croce
o0201084.006vb 1423/4 febbraio 18 Term of payment for debt for property gabelle. quartiere di Santa Maria Novella
o0201084.007va 1423/4 febbraio 23 Concession of fir lumber to the wardens of Santa Croce for their dormitory. Santa Croce dell'ordine di San Francesco
o0201084.009a 1423/4 febbraio 29 Reduction of the price of unsold lumber, to take effect after the Opera of Santa Croce takes the quantity assigned to it. Opera di Santa Croce
o0201084.009c 1423/4 marzo 11 Term of payment for debt for property gabelle and release of arrested persons. quartiere di Santa Croce
o0201084.011c 1424 marzo 28 Term of payment to possessor of properties of arrested debtor and his release. quartiere di Santa Maria Novella
o0201084.012vb 1424 aprile 4 Order to make two glass oculi in the central nave on design by Lorenzo Ghiberti. ordine dei frati predicatori di Santa Maria Novella
o0201084.016vb 1424 giugno 16 Letter to the Podestà of the League of Mangona in favor of the Commune of Santa Reparata to Pimonte for wine and butchering taxes imposed on the Commune and owing to the League. Comune di Santa Reparata a Pimonte
o0201084.016vc 1424 giugno 16 Right of recourse to a person enjoined to pay for the parish of Santa Maria a Fagna. popolo di Santa Maria a Fagna
o0201084.065a 1423/4 gennaio 10 Guaranty for holder of properties of debtors. quartiere di Santa Croce
o0201084.065b 1423/4 gennaio 10 Guaranty for debt for pardons of forced loans. quartiere di Santa Croce, gonfalone del Carro
o0201084.065vf 1424 marzo 29 Guaranty for holder of properties of debtor. quartiere di Santa Maria Novella
o0201084.066d 1424 aprile 27 Guaranty for unspecified debt. quartiere di Santa Maria Novella
o0201084.075c 1423/4 gennaio 19 Arrest for unspecified debt. quartiere di Santa Croce
o0201084.075vc 1424 marzo 27 Arrest for unspecified debt. quartiere di Santa Maria Novella
o0201084.075vd 1424 aprile 27 Arrest for debt for forced loans. quartiere di Santa Maria Novella
o0201085.003vd 1424 novembre 22 Letter with summons for debt for property gabelle. quartiere di Santa Maria Novella
o0201085.066b 1424 novembre 17 Guaranty for debt for forced loans. quartiere di Santa Maria Novella
o0201085.066va 1424/5 febbraio 6 Guaranty for unspecified debt. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0201085.075c 1424 ottobre 5 Arrest for unspecified debt. quartiere di Santa Maria Novella
o0201086.002e 1424/5 gennaio 24 Order to demand payment of the possessors of the debtor's properties for testamentary bequest with distraint. quartiere di Santa Maria Novella
o0201086.002va 1424/5 gennaio 24 Term of payment for debt for gabelles with guaranty and restitution of pawns. quartiere di Santa Maria Novella, gonfalone del Leone bianco
o0201086.003c 1424/5 gennaio 29 Resolution for demand payment of possessors of property by testamentary legacies in favor of the hospital of Santa Maria della Scala. ospedale di Santa Maria della Scala
o0201086.003c 1424/5 gennaio 29 Resolution for demand payment of possessors of property by testamentary legacies in favor of the hospital of Santa Maria della Scala. quartiere di Santa Croce
o0201086.005b 1424/5 febbraio 27 Dismissal of debt collector with order to give back payment demanded for testament. quartiere di Santa Maria Novella
o0201086.011b 1425 aprile 14 Term of payment to the Commune of Santa Croce for debt for pardons of forced loans. Comune di Santa Croce Valdarno di sotto
o0201086.011vb 1425 aprile 14 Term of payment for property gabelle of the priests with obligation of guaranty. badia di Santa Maria a Trebbio
o0201086.015vc 1425 maggio 16 Term of payment for unspecified debt. quartiere di Santa Maria Novella
o0201086.020a 1425 giugno 1 Term of payment for debt with obligation of guaranty. quartiere di Santa Croce
o0201086.031a 1424/5 marzo 15 Rent of the shop called Galea to Fra Bernardo master of glass oculi with deadline for inception of work on the stained-glass windows. ordine dei frati predicatori di Santa Maria Novella
o0201086.043c 1424/5 gennaio 29 Payment for the purchase of house in partial compensation for damages to the rector of Santa Cecilia. chiesa di Santa Cecilia
o0201086.043d 1424/5 gennaio 29 Payment for the purchase of land in partial compensation of damages to the rector of Santa Cecilia. chiesa di Santa Cecilia
o0201086.048a 1425 aprile 20 Payment to master of glass oculi via letter of exchange to Venice. ordine dei frati predicatori di Santa Maria Novella
o0201086.049b 1425 maggio 16 Payment for the purchase of glass in Venice to make oculi. ordine dei frati predicatori di Santa Maria Novella
o0201086.070b 1424/5 marzo 1 Guaranty for contract for glass oculi. ordine dei frati predicatori di Santa Maria Novella
o0201086.071vd 1425 aprile 18 Term of payment for debt for property gabelle with corresponding guaranty and annotation of prior payment. badia di Santa Maria a Trebbio a Monte Cornaro
o0201086.072e 1425 maggio 16 Term of payment to heir of debtor with guaranty. quartiere di Santa Maria Novella
o0201086.072vc 1425 giugno 1 Guaranty for unspecified debt. quartiere di Santa Croce
o0201086.086b 1425 aprile 17 Arrest for debt for property gabelle of priests. badia di Santa Maria a Trebbio
o0201086.086ve 1425 maggio 9 Arrest of debtor for property gabelle of priests. pieve di Santa Maria a Cappiano
o0201086.086vf 1425 maggio 9 Guaranty for debt of rector. pieve di Santa Maria a Cappiano
o0201086.087c 1425 maggio 11 Arrest of (heir) of debtor and his release by resolution of the wardens. quartiere di Santa Maria Novella
o0201086.087vb 1425 maggio 22 Arrest for debt for property gabelle and pardons of forced loans. quartiere di Santa Croce
o0201086.087vc 1425 maggio 22 Distraint to debtor. quartiere di Santa Maria Novella
o0202001.005a 1425 agosto 7 Term of payment. quartiere di Santa Croce
o0202001.005f 1425 agosto 7 Term of payment. quartiere di Santa Croce
o0202001.005h 1425 agosto 7 Term of payment for debt for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0202001.005va 1425 agosto 7 Prohibition to demand payment and cancellation of debt registered twice. quartiere di Santa Croce, gonfalone del Leone nero
o0202001.005vf 1425 agosto 7 Term of payment for debt for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0202001.008vf 1425 agosto 22 Term of payment given to debtors. quartiere di Santa Maria Novella
o0202001.009vd 1425 settembre 18 Term of payment to possessors of properties. quartiere di Santa Maria Novella
o0202001.012vb 1425 ottobre 31 Term of payment for debt for forced loans. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0202001.012vc 1425 ottobre 31 Prohibition to demand payment, cancellation of debt and restitution of pawns. quartiere di Santa Maria Novella
o0202001.012vf 1425 novembre 3 Term of payment to the baptismal parish of Santa Maria Impruneta. piviere di Santa Maria Impruneta
o0202001.017a 1425 novembre 23 Term of payment for debt for forced loans. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0202001.018vb 1425 dicembre 13 Term of payment. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0202001.024b 1425/6 marzo 12 Term of payment given to debtors. quartiere di Santa Croce
o0202001.025vi 1425/6 marzo 21 Unfinished act concerning a debtor. quartiere di Santa Maria Novella
o0202001.037c 1426 luglio 17 Term of payment for debt to the prior of Santa Maria a Vigesimo. chiesa di Santa Maria a Vigesimo
o0202001.046f 1426 novembre 29 Letter to preaching friar ordering him to come to give explanations. ordine dei frati minori di Santa Croce
o0202001.053vc 1426/7 marzo 6 Term of payment and revocation of demand of payment for debt. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0202001.054vh 1427 aprile 2 Term of payment to chaplain. Santa Reparata, cappella di Santa Cecilia
o0202001.054vh 1427 aprile 2 Term of payment to chaplain. Santa Reparata, cappella di Santa Cecilia
o0202001.071f 1427 ottobre 30 Authority to the administrator to purchase a house from the superintendent of Santa Maria Nuova. ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze
o0202001.073b 1427 dicembre 4 Order to the master builder to have a sink repaired. ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze
o0202001.082i 1428 aprile 30 Term of payment to heirs for the payment of legacies. quartiere di Santa Croce
o0202001.085e 1428 maggio 28 Authority to the administrator to rent out a house it has purchased to its present occupant. ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze
o0202001.092m 1428 ottobre 1 Exemption allowed to heirs for gabelle on contracts. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0202001.095va 1428 dicembre 23 Sentence regarding a bequest made to the Opera of dotal properties of testator's sister, recognized as property of other legitimate heirs. ospedale di Santa Maria della Misericordia d'Arezzo
o0202001.099va 1428/9 gennaio 28 Election of lawyer and release of heirs from overly burdensome testamentary legacies and their acquittal. ospedale di Santa Maria della Misericordia di Arezzo
o0202001.100vh 1428/9 febbraio 18 Term of payment given to debtors. (Firenze), quartiere di Santa Maria Novella
o0202001.102va 1428/9 febbraio 23 Authorization to cancel debtor and term of payment to newly registered replacement. quartiere di Santa Maria Novella
o0202001.103b 1428/9 marzo 12 Term of payment given to a debtor. quartiere di Santa Croce
o0202001.108vg 1429 luglio 5 Assignment of house to (canon). ordine dei frati minori di Santa Croce
o0202001.115vd 1429 ottobre 26 Cancellation of debit entry registered twice. (quartiere) di Santa Croce
o0202001.118e 1429 dicembre 2 Term of payment for debt for forced loans. quartiere di Santa Maria Novella
o0202001.127l 1430 maggio 19 Letter to the Podestà of San Gimignano to demand payment of debt from the hospital of Santa Maria della Scala. ospedale di Santa Maria della Scala di San Gimignano
o0202001.131vb 1430 settembre 18 Authorization to cut lumber in the forest of the Opera for the hospital of Santa Maria degli Innocenti. ospedale di Santa Maria degli Innocenti
o0202001.131vb 1430 settembre 18 Authorization to cut lumber in the forest of the Opera for the hospital of Santa Maria degli Innocenti. Arte di Por Santa Maria
o0202001.140g 1431 aprile 13 Revocation in part of demand of payment. popolo di Santa Maria di Poggitazzi
o0202001.160vb 1432 maggio 14 Revocation of a demand of payment for reasons of dowry. quartiere di Santa Croce
o0202001.166d 1432 luglio 18 Term of payment to the hospital of the Innocenti for lumber sold. Arte di Por Santa Maria
o0202001.166ve 1432 luglio 30 Authorization to the administrator to lend a saw. convento di Santa Croce
o0202001.169h 1432 settembre 5 Permission to a master to work at Santa Maria Nuova. ospedale di Santa Maria Nuova
o0202001.177ve 1431 dicembre 23 Partition of a house in order to make lodgings for two canons and assignment of one part. ospedale di Santa Maria Nuova
o0202001.178c 1432 settembre 26 Permission to the consuls of the guild of Por Santa Maria to cut firewood in the forest of the Opera. Arte di Por Santa Maria
o0202001.180a 1435 aprile 22 Authorization to cut lumber of the forest for the hospital of the Innocenti. Arte di Por Santa Maria
o0202001.180c 1435 ottobre 8 Authorization to have lumber of the forest cut for the hospital of the Innocenti. Arte di Por Santa Maria
o0202001.188vd 1432 ottobre 14 Sale of a column of marble. chiesa di Santa Maria a Rignalla
o0202001.190b 1432 ottobre 31 Term of payment for debt. piviere di Santa Maria Impruneta
o0202001.190va 1432 novembre 19 Term of payment with obligation of guaranty. piviere di Santa Maria Impruneta
o0202001.191vd 1432 dicembre 3 Extinction of demand of payment and new procedure of notification of debt for the hospital of Santa Maria Nuova. ospedale di Santa Maria Nuova
o0202001.194vb 1432 dicembre 27 Sale to the hospital of Santa Maria Nuova for a house let to the notary of the Opera. ospedale di Santa Maria Nuova
o0202001.203ve 1433 luglio 21 Election of the lawyer of the Opera as consultant for a litigation with the hospital of the Scala. ospedale di Santa Maria della Scala
o0202001.212e 1433/4 marzo 24 Revocation of demand of payment against the hospital of Santa Maria della Scala, heir of a debtor of the Opera. ospedale di Santa Maria della Scala
o0202001.213c 1434 aprile 5 Restitution of pawns to the hospital of Santa Maria della Scala. ospedale di Santa Maria della Scala
top of page Return Help Contact home
© 2015 Opera di Santa Maria del Fiore