space Studies
italian
english
space Sources Dates Indices Topics1 Topics2 Reference Texts


NAMESANDROLES


SURNAMESETC.


WordsinNAMESANDROLES


PLACES


WordsinPLACES


INSTITUTIONS


WordsinINSTITUTIONS


A-E


F-K


L-O


P-S

T-Z


OTHER

1-150 A151-300  A301-364 


Previous
Santa
Next
 

sorted
Document

sort
Date

sort
Summary

sort
Context of query
o0201070.003vd 1416/7 gennaio 14 Restitution of the book of the constitutions to the canons with the obligation to keep it chained in the sacristy. canonici di Santa Maria del Fiore
o0201070.005d 1416/7 gennaio 25 Sale of a small slab of white marble. monastero di Santa Verdiana di Firenze
o0201070b.002vb 1416/7 gennaio 8 Letter to the Podestà of Santa Croce for investigation on debt for pasturage animals in said Commune. Comune di Santa Croce Valdarno
o0201070b.004e 1416/7 gennaio 25 Term of payment for property gabelle to the monastery of Santa Cristiana of Santa Croce. monastero di Santa Cristiana a Santa Croce Valdarno
o0201070b.004e 1416/7 gennaio 25 Term of payment for property gabelle to the monastery of Santa Cristiana of Santa Croce. monastero di Santa Cristiana a Santa Croce Valdarno
o0201070b.004vd 1416/7 gennaio 26 Term of payment and release of arrested person for the hospital of Santa Fina and for the Opera of Santa Maria of San Gimignano. ospedale di Santa Fina di San Gimignano
o0201070b.004vd 1416/7 gennaio 26 Term of payment and release of arrested person for the hospital of Santa Fina and for the Opera of Santa Maria of San Gimignano. Opera di Santa Maria di San Gimignano
o0201070b.006d 1416/7 febbraio 9 Term of payment for debt for new gabelles. chiesa di Santa Maria Maggiore di Firenze
o0201070b.015vf 1416/7 marzo 24 Term of payment to the parish of Santa Maria di Vincigliata with release of arrested person upon provision of guaranty. popolo di Santa Maria di Vincigliata
o0201070b.019vb 1417 aprile 29 Term of payment for debt for new gabelles of the monastery of Santa Croce di Fagna. monastero di Santa Croce di Fagna
o0201070b.022vf 1417 maggio 26 Term of payment for unspecified debt to the abbeys of Pontenano and Loro. badia di Santa Trinita a Pontenano
o0201070b.049vc 1416/7 gennaio 18 Guaranty for debt for new gabelles of the hospital of Santa Fina and the Opera of San Gimignano. ospedale di Santa Fina di San Gimignano
o0201070b.050vb 1416/7 gennaio 26 Guaranty for unspecified debts for the hospital of Santa Fina and the Opera of Santa Maria of San Gimignano. ospedale di Santa Fina di San Gimignano
o0201070b.050vb 1416/7 gennaio 26 Guaranty for unspecified debts for the hospital of Santa Fina and the Opera of Santa Maria of San Gimignano. Opera di Santa Maria pieve di San Gimignano
o0201070b.056vb 1417 marzo 26 Guaranty for unspecified debt of the parish of Santa Maria di Vincigliata. popolo di Santa Maria di Vincigliata
o0201070b.057ve 1417 aprile 21 Guaranty for balance of debt for property gabelle of the parish of Santa Maria of Dicomano. popolo di Santa Maria di Dicomano
o0201070b.060b 1417 maggio 26 Guaranty for unspecified debts of the abbeys of Pontenano and Loro. badia di Santa Trinita a Pontenano
o0201070b.060vd 1417 giugno 8 Guaranty for debt for new gabelles. monastero di Santa Croce di Fagna
o0201070b.061vf 1417 giugno 30 Guaranty for debt for property gabelle. quartiere di Santa Maria Novella, gonfalone dell'Unicorno
o0201070b.062a 1417 luglio 2 Guaranty for debt for new gabelles of the ecclesiastical establishsments of the Podesteria of Verghereto. badia di Santa Maria a Trivio
o0201070b.074h 1417 maggio 18 Arrest for debt for property gabelle of the parish of Santa Maria di Vincigliata and for Castellina. popolo di Santa Maria di Vincigliata
o0201070b.077d 1416/7 gennaio 18 Arrest for debt for property gabelle of the hospital of Santa Fina and of the Opera of San Gimignano. ospedale di Santa Fina di San Gimignano
o0201070b.078d 1416/7 gennaio 22 Arrest for debt for property gabelle of the third year of the parishes of Santa Maria di Pinzano and Santo Stefano alla Torre. popolo di Santa Maria di Pinzano
o0201070b.082c 1416/7 marzo 18 Arrest for debt for new gabelles of the parish of Santa Maria di Aceraia. popolo di Santa Maria di Aceraia
o0201070b.083b 1416/7 marzo 16 Arrest for debt for property gabelle of the parish of Santa Maria di Vincigliata and for the second installment of Castellina. popolo di Santa Maria di Vincigliata
o0201070b.083vc 1417 marzo 26 Arrest for debt for property gabelle of the parish of Santa Maria a Pogi. popolo di Santa Maria a Pogi
o0201070b.085c 1416/7 marzo 8 Arrest for debt for milling gabelle. popolo di Santa Maria di Carraia
o0201070b.087c 1417 giugno 17 Arrest for debt for pardons of gabelles. popolo di Santa Lucia d'Ognissanti fuori le mura
o0201070b.087f post 1417 giugno 18 Arrest for debt for pardons of gabelles. popolo di Santa Maria a Querceto
o0201070b.089vd 1417 aprile 24 Arrest for debt for pardons of gabelles of the parish of Santa Maria a Quinto. popolo di Santa Maria a Quinto
o0201070b.094a 1417 giugno 3 Arrest for debt for forced loans with release of the arrested person because not the debtor. quartiere di Santa Croce
o0201070b.096va post 1416/7 gennaio 1 Annotation concerning debt for property gabelle. quartiere di Santa Maria Novella
o0201070b.096vi 1417 luglio 5 Annotation concerning debt for gabelle. (quartiere di) Santa Croce
o0201070b.096vs 1417 luglio 6 Annotation concerning debt for forced loans. (quartiere di) Santa Croce
o0201070b.096vu 1417 luglio 6 Annotation concerning balance of debt for property gabelle. (quartiere di) Santa Maria Novella
o0201072.016e 1417/8 gennaio 27 Term of payment for debt. popolo di Santa Maria a Monte Macerata
o0201072.021vg 1417/8 febbraio 25 Term of payment and corresponding guaranty. chiesa di Santa Maria in Pilli
o0201072.026vh 1417/8 marzo 17 Term of payment for pardons. popolo di Santa Maria a Settignano
o0201072.032d 1418 aprile 6 Election of the messengers and setting of their salary with guaranties. quartiere di Santa Maria Novella
o0201072.033a 1417 novembre 10 Arrests for debts. popolo di Santa Maria a Quinto
o0201072.033a 1417 novembre 10 Arrests for debts. popolo di Santa Maria a Tizzana
o0201072.037a 1417 novembre 19 Arrests for debts. popolo di Santa Maria a Dicomano
o0201072.040a 1417/8 gennaio 10 Arrests for debts. popolo della pieve di Santa Maria a Cilicciavole
o0201072.040a 1417/8 gennaio 10 Arrests for debts. popolo di Santa Margherita a Tosina
o0201072.047va 1418 aprile 7 Arrests for debts. popolo della pieve di Santa Felicita a Larciano
o0201072.047va 1418 aprile 7 Arrests for debts. popolo di Santa Maria a Petriolo
o0201073.002a 1418 aprile 11 Revocation of the taxation made against the church of Campo a Romena. chiesa di Santa Margherita di Campolombardo a Romena
o0201073.003b 1418 aprile 13 Term of payment for pardon of taxes and for the tax on wine with release of arrested person. popolo di Santa Felicita a Larciano
o0201073.003b 1418 aprile 13 Term of payment for pardon of taxes and for the tax on wine with release of arrested person. piviere di Santa Felicita a Larciano
o0201073.003vd 1418 aprile 16 Term of payment and release of a person arrested for the parish of Santa Maria d'Aceraia. popolo di Santa Maria d'Aceraia
o0201073.009va 1418 maggio 6 Term of payment for pardons of taxes to the parish of Santa Maria a Sammontana. popolo di Santa Maria a Sammontana
o0201073.016c 1418 aprile 13 Guaranty for debt for pardons of taxes. popolo di Santa Felicita a Larciano
o0201073.016c 1418 aprile 13 Guaranty for debt for pardons of taxes. piviere di Santa Felicita a Larciano
o0201073.017a 1418 maggio 6 Guaranty for debt for pardons of taxes. popolo di Santa Maria a Sammontana
o0201073.032a 1418 aprile 13 Arrests for debts. popolo di Santa Maria a Quinto
o0201073.036a 1418 aprile 12 Arrests for debts. popolo della pieve di Santa Maria Impruneta
o0201073b.003e 1418 aprile 18 Tax determined for a farm with two owners. monastero di Santa Felicita
o0201074.005d 1418 agosto 6 Promise of payment and release of arrested person. chiesa di Santa Maria degli Angeli di Castrocaro
o0201074.008c 1418 agosto 12 Reduction of tax on the confraternity of the Misericordia. compagnia di Santa Maria della Misericordia di Firenze
o0201074.009d 1418 agosto 19 Authorization to purchase a house. ospedale di Santa Maria Nuova
o0201074.011d 1418 agosto 26 Cancellation of a tax on livestock because of exemption in the commune where it is kept. Comune di Santa Croce
o0201074.011d 1418 agosto 26 Cancellation of a tax on livestock because of exemption in the commune where it is kept. Comune di Santa Maria a Monte
o0201074.020vc 1418 settembre 26 Letter to the Podestà of Laterina for confiscation of properties and term of payment for the new gabelles. badia di Santa Trinita d'Alpe di Pontenano
o0201074.045vd 1418 agosto 6 Guaranty for debt. chiesa di Santa Maria degli Angeli di Castrocaro
o0201074.049d 1418 agosto 26 Guaranty for debt for forced loans. quartiere di Santa Maria Novella
o0201075.003c 1418/9 gennaio 11 Cancellation of double registration for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0201075.007d 1418/9 febbraio 8 Exemption and release of arrested persons for portions of inheritance due to various hospitals and demand of payment of another heir for remaining quota. ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze
o0201075.007d 1418/9 febbraio 8 Exemption and release of arrested persons for portions of inheritance due to various hospitals and demand of payment of another heir for remaining quota. ospedale di Santa Maria della Scala
o0201075.008vd 1418/9 febbraio 14 Restitution of money with commission. chiesa di Santa Cecilia di Firenze
o0201075.015vc 1419 aprile 3 Term of payment for debt for forced loans and property gabelle with deduction of gabelle erroneously paid twice. quartiere di Santa Maria Novella
o0201075.015vc 1419 aprile 3 Term of payment for debt for forced loans and property gabelle with deduction of gabelle erroneously paid twice. quartiere di Santa Croce, gonfalone Leone nero
o0201075.027c 1419 maggio 10 Term of payment for debt for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0201075.031vf 1419 giugno 2 Term of payment for property gabelle to the church of Santa Cristina a Pilli and the altar of San Giovanni di Carmignano. chiesa di Santa Cristina a Pilli
o0201075.070vb 1418/9 gennaio 25 Guaranty for debt for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0201075.071e 1418/9 febbraio 3 Guaranty for debt of the baptismal parish of Santa Maria of San Miniato. pieve di Santa Maria di San Miniato
o0201075.073c 1418/9 marzo 16 Guaranty for debt for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0201075.073ve 1419 aprile 4 Guaranty for debt for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0201075.075f 1419 aprile 26 Guaranty for debt. quartiere di Santa Croce
o0201075.075vf 1419 maggio 11 Guaranty for debt for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0201075.076b 1419 maggio 13 Guaranty for debt for forced loans. chiesa di Santa Maria Novella di Firenze
o0201075.077va 1419 giugno 3 Guaranty for debt for property gabelle of the church of Santa Cristina a Pilli. chiesa di Santa Cristina a Pilli
o0201075.077va 1419 giugno 3 Guaranty for debt for property gabelle of the church of Santa Cristina a Pilli. altare di San Giovanni in Santa Cristina
o0201076.004ve 1419 luglio 12 Cancellation of debt for forced loans due to registration in two quarters. quartiere di Santa Maria Novella
o0201076.006va 1419 luglio 19 Oath of warden and term of payment. popolo di Santa Maria a Monte Macerata
o0201076.007vb 1419 agosto 2 Term of payment for property gabelle with right of recourse against the first owners and exemption from demand of payment for donation. ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze
o0201076.009vc 1419 agosto 11 Cancellation of debt for property gabelle because discounted for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0201076.013va 1419 settembre 6 Revocation of demand of payment on properties for dotal rights and for renunciation of inheritance. quartiere di Santa Maria Novella
o0201076.016vf 1419 settembre 20 Term of payment to nine communes of the Podesteria of Santa Maria a Trebbio. Podesteria di Santa Maria a Trebbio
o0201076.018ve 1419 ottobre 7 Term of payment for debt to the churches of San Giusto a Ema and of Santa Maria a Carpineto. chiesa di Santa Maria a Carpineto
o0201076.031a 1419 novembre 21 Term of payment to the Commune of Santa Luce. Comune di Santa Luce
o0201076.033va 1419 dicembre 14 Cancellation of debt for property gabelle paid for forced loans under another name. quartiere di Santa Maria Novella
o0201076.034c 1419 dicembre 14 Term of payment to the priory of Santa Maria a Mosciano for debt for property gabelle with guaranty. prioria di Santa Maria a Mosciano
o0201076.070d 1419 luglio 3 Guaranty for a debt. popolo di Santa Maria a Poneta
o0201076.071vc 1419 luglio 21 Guaranty for the parish of Santa Maria di Monte Macerata for debt for property gabelle. popolo di Santa Maria a Monte Macerata
o0201076.073vd 1419 ottobre 10 Guaranty for debt of the churches of San Giusto a Ema and Santa Maria a Carpineto. (chiesa di) Santa Maria a Carpineto
o0201076.076d 1419 novembre 26 Guaranty for debt of the Commune of Santa Luce. Comune di Santa Luce
o0201077.006vf 1419/20 gennaio 10 Temporary revocation of demand of payment from the church of Santa Maria del Piano for debt for new gabelles and summons of the men of said parish indicated as true debtors. chiesa di Santa Maria del Piano di Cascia
o0201077.008ve 1419/20 gennaio 18 Prohibition to demand payment of debt for forced loans and correction of sum erroneously debited twice. quartiere di Santa Croce
o0201077.011a 1419/20 gennaio 23 Term of payment for debt for properties taxed and correction of entry in favor of the church of Santa Maria del Piano di Cascia. popolo di Santa Maria del Piano
o0201077.011a 1419/20 gennaio 23 Term of payment for debt for properties taxed and correction of entry in favor of the church of Santa Maria del Piano di Cascia. chiesa di Santa Maria del Piano di Cascia
o0201077.016e 1419/20 febbraio 7 Term of payment to the parish of Santa Croce in Mugello for debt for gabelle on properties and persons. popolo di Santa Croce del Mugello
o0201077.018b 1419/20 febbraio 9 Cancellation of debt of the church of Santa Maria di Limite and restitution of pawns to its laborer. chiesa di Santa Maria di Limite
o0201077.019vb 1419/20 febbraio 13 Term of payment to the hospital of Santa Maria Nuova. ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze
o0201077.020vb 1419/20 febbraio 21 Authorization to tenant to pay the same rent paid to the previous owner. ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze
o0201077.021vd 1419/20 febbraio 23 Approval of previous resolution for the purchase of a house from the hospital of Santa Maria Nuova. ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze
o0201077.023va 1419/20 febbraio 29 Cancellation of debt for property gabelle and correction of account entry written twice. quartiere di Santa Croce
o0201077.026d 1419/20 marzo 9 Term of payment for debt for forced loans and release of the arrested debtor. quartiere di Santa Maria Novella
o0201077.028a 1419/20 marzo 19 Term of payment for debt for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0201077.028c 1419/20 marzo 21 Term of payment to the parish of Santa Maria di Monte Macerata for gabelle on properties and release of arrested person. popolo di Santa Maria di Monte Macerata
o0201077.039a 1420 aprile 30 Correction of account entry for debt for new gabelles. monastero di Santa Chiara di Firenze
o0201077.044a 1420 giugno 12 Cancellation of a debt already paid. popolo di Santa Maria a Quinto
o0201077.047ve 1420 giugno 28 Authorization to deduct payment for property gabelle from a debt for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0201077.052vd 1419 dicembre 29 Payment for the purchase of a house from the hospital of Santa Maria Nuova. ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze
o0201077.084vf 1419/20 marzo 23 Guaranty for the parish of Santa Maria di Monte Macerata for debt. popolo di Santa Maria di Monte Macerata
o0201078.004a 1420/1 gennaio 22 Release of arrested person for debt of the baptismal parishes of Borgo San Lorenzo and Santa Felicita a Larciano. pieve di Santa Felicita a Larciano
o0201078.004d 1420/1 gennaio 23 Approval of guarantor for debt for property gabelle. pieve di Santa Felicita a Larciano
o0201078.005va 1420/1 gennaio 24 Term of payment for balance of gabelle on property and persons to the parish of Santa Maria a Marcoiano. popolo di Santa Maria a Marcoiano
o0201078.005vb 1420/1 gennaio 24 Concession of right of recourse to a person enjoined to pay the debt for the property gabelle of the parish of Santa Maria a Marcoiano. popolo di Santa Maria a Marcoiano
o0201078.009c 1420/1 febbraio 17 Term of payment for forced loans without restitution of pawns. quartiere di Santa Maria Novella
o0201078.011va 1420/1 marzo 10 Authorization to the administrator to sell stones to the Opera of Santa Croce to make an oculus. Opera di Santa Croce
o0201078.013vc 1420/1 marzo 15 Detention of the messenger of a confraternity that meets in Santa Maria Novella for missing restitution of logs. compagnia che si raduna in Santa Maria Novella
o0201078.020d 1421 aprile 7 Term of payment to the communes of the Podesterias of Santa Maria al Trebbio, Rasignano and Vico. comuni della Podesteria di Santa Maria al Trebbio
o0201078.034vb 1421 maggio 30 Term of payment for debt for forced loans and property gabelle. quartiere di Santa Croce
o0201078.038ve 1421 giugno 10 Term of payment for debt for property gabelle to the parish of Santa Maria di Monte Macerata with release of the guarantor. popolo di Santa Maria a Monte Macerata
o0201078.082e 1420/1 gennaio 22 Guaranty for debt for property gabelle of Borgo San Lorenzo and Santa Felicita a Larciano. pieve di Santa Felicita a Larciano
o0201078.082va 1420/1 gennaio 24 Guaranty for debt for property gabelle and for tax on persons for milling of Santa Maria to Marcoiano. popolo di Santa Maria a Marcoiano
o0201079.021vc 1421 agosto 30 Term of payment to the communes of the Podesteria of Santa Maria a Trebbio. comuni della Podesteria di Santa Maria a Trebbio
o0201079.031d 1421 ottobre 11 Extension of term of payment to the church of Santa Maria a Pulicciano. chiesa di Santa Maria a Pulicciano
o0201079.035va 1421 ottobre 27 Term of payment to the hospital of the Bigallo of Ruballa for property gabelle with guaranty and restitution of pawns. ospedale di Santa Maria del Bigallo di Ruballa
o0201079.037a 1421 ottobre 27 Declaration for Santa Maria and San Biagio a Ciggiano; unfinished act. Santa Maria e San Biagio di Ciggiano
o0201079.037va 1421 ottobre 30 Term of payment for property gabelle to the monastery of Santa Croce of the lower Valdarno. monastero di Santa Croce di Valdarno di sotto
o0201079.042vb 1421 novembre 17 Cancellation of debt for property gabelle erroneously debited and registration of the debt to whoever is responsible. chiesa di Santa Maria a Ciggiano
o0201079.044vd 1421 novembre 21 Term of payment for property gabelle to the hospital of Santa Maria del Pellegrinaggio. ospedale di Santa Maria del Pellegrinaggio
o0201079.045ve 1421 novembre 26 Cancellation of balance of debt for forced loans. quartiere di Santa Croce
o0201079.048vd 1421 dicembre 9 Term of payment for unspecified debt. quartiere di Santa Croce
o0201079.049c 1421 dicembre 5 Term of payment for unspecified debt. quartiere di Santa Croce
o0201079.049f 1421 dicembre 5 Sale of stones to the hospital of Santa Maria Nuova. ospedale di Santa Maria Nuova
o0201079.050vd 1421 dicembre 19 Cancellation of debt for property gabelle registered in two urban districts. quartiere di Santa Maria Novella
o0201079.072a 1421 agosto 22 Compensation to messer Benozzo Federighi canon and rector of Santa Cecilia for properties destroyed to make the square of the Signori. chiesa di Santa Cecilia di Firenze
o0201079.082vg 1421 luglio 11 Guaranty for debt for forced loans. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0201079.083vg 1421 luglio 29 Guaranty for unspecified debts of the communes of the baptismal parish of Calci, of Santa Maria di Guigliarda, of San Michele di Ghezzano, of San Prospero, of Colignola, of Mezzana, of San Vittorio, of San Michele di Castello Maggiore, of Montemagno, of San Giusto a Campo and of Bagno of Monte Pisano. Comune di Santa Maria di Guigliarda
o0201079.084vb 1421 agosto 9 Guaranty for unspecified debts for the parishes of San Bartolo di Castello and of Santa Croce di Dicomano. popolo di Santa Croce di Dicomano
o0201079.085vc 1421 agosto 30 Guaranty for debt for forced loans of the monastery of San Piero Martire. quartiere di Santa Maria Novella
o0201079.085vd 1421 agosto 30 Guaranty for debt for pardons and contracts of the communes of the Podesteria of Santa Maria a Trebbio. comuni della Podesteria di Santa Maria a Trebbio
o0201079.087va 1421 ottobre 27 Guaranty for debt for property gabelle of the hospital of Santa Maria of the Bigallo of Ruballa. ospedale di Santa Maria del Bigallo di Ruballa
o0201079.087vf 1421 novembre 19 Guaranty for unspecified debt. quartiere di Santa Maria Novella
o0201079.088g 1421 novembre 22 Guaranty for debt for property gabelle of the hospital of Santa Maria del Pellegrinaggio. ospedale di Santa Maria del Pellegrinaggio
o0201079.088vf 1421 dicembre 1 Guaranty for debt for property gabelle of the monastery of Santa Croce Valdarno. monastero di Santa Croce di Valdarno
o0201079.089c 1421 dicembre 10 Guaranty for unspecified debt. quartiere di Santa Croce
o0201079.089e 1421 dicembre 16 Guaranty for unspecified debt. quartiere di Santa Croce
top of page Return Help Contact home
© 2015 Opera di Santa Maria del Fiore