space Studies
italian
english
space Sources Dates Indices Topics1 Topics2 Reference Texts


NAMESANDROLES


SURNAMESETC.


WordsinNAMESANDROLES


PLACES


WordsinPLACES


INSTITUTIONS


WordsinINSTITUTIONS


A-E

F-K


L-O


P-S


T-Z


OTHER

A1-150  A151-300  A301-450  A451-600  A601-750  A751-900  A901-1050  A1051-1200  A1201-1350  A1351-1500  A1501-1650  A1651-1800  A1801-1950  A1951-2100  A2101-2250  A2251-2400  A2401-2550  A2551-2700  2701-2850 A2851-3000  A3001-3150  A3151-3300  A3301-3450  A3451-3600  A3601-3750  A3751-3826 


Previous
di
Next
 

sort
Document

sorted
Date

sort
Summary

sort
Context of query
o0202001.010f 1425 settembre 26 Election of the administrator of the construction of the castle of Malmantile with salary set. Lega di Gangalandi
o0202001.010va 1425 settembre 26 Election of the administrator of the castle of Lastra with salary set. Comune di Gangalandi
o0202001.010vc 1425 settembre 26 Letter to the Captain of Pistoia for demand of payment of the treasurer of the Commune. Comune di Pistoia
o0202001.010vd 1425 settembre 26 Term assigned to the adversary in a dispute for the presentation of his rights and authority to the notary of the Opera for the election of a lawyer. Comune di Cesano
o0202001.010vd 1425 settembre 26 Term assigned to the adversary in a dispute for the presentation of his rights and authority to the notary of the Opera for the election of a lawyer. corte del vicario di Vicopisano
o0202001.011c 1425 ottobre 12 Term of payment to the Commune of San Miniato fiorentino. Comune di San Miniato fiorentino
o0202001.011vc 1425 ottobre 12 Term of payment to guarantor. quartiere di San Giovanni
o0202001.011vf 1425 ottobre 12 Term of payment for debt for forced loans. quartiere di Santo Spirito
o0204009.111a 1425 ottobre 12 Balance of payment to the Ten of Pisa for legislation of the magnifici Signori of (Florence). Dieci di Pisa
o0204009.111a 1425 ottobre 12 Balance of payment to the Ten of Pisa for legislation of the magnifici Signori of (Florence). Signori di (Firenze)
o0204011.072ve 1425 ottobre 12 Term of payment to the Commune of San Miniato. Comune di San Miniato
o0202001.012b 1425 ottobre 22 Term of payment to the Commune of Buggiano. Comune di Buggiano
o0202001.012c 1425 ottobre 22 Term of payment to guarantor. quartiere di Santo Spirito
o0202001.012d 1425 ottobre 22 Term of payment for debt. quartiere di Santo Spirito
o0202001.012e 1425 ottobre 22 Term of payment to the Commune of Montevarchi. Comune di Montevarchi
o0204011.073b 1425 ottobre 22 Term of payment given to a debtor. (quartiere) di San Giovanni
o0204011.073d 1425 ottobre 22 Term of payment to the Commune of Buggiano. Comune di Buggiano
o0204011.073e 1425 ottobre 22 Term of payment given to a debtor. quartiere di Santo Spirito
o0204011.073f 1425 ottobre 22 Term of payment given to a debtor. (quartiere) di Santo Spirito
o0204011.073g 1425 ottobre 22 Term of payment to the Commune of Montevarchi for retail wine gabelle. Comune di Montevarchi
o0202001.003h 1425 ottobre 25 Term of payment given to a debtor. quartiere di Santo Spirito
o0202001.012h 1425 ottobre 31 Credit to the Commune of Cerreto of sum paid twice and restitution of deposit. Popolo e Comune di Firenze
o0202001.012h 1425 ottobre 31 Credit to the Commune of Cerreto of sum paid twice and restitution of deposit. Comune di Firenze
o0202001.012h 1425 ottobre 31 Credit to the Commune of Cerreto of sum paid twice and restitution of deposit. Comune di Cerreto
o0202001.012vb 1425 ottobre 31 Term of payment for debt for forced loans. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0202001.012vc 1425 ottobre 31 Prohibition to demand payment, cancellation of debt and restitution of pawns. corte del Podestà di Firenze
o0202001.012vc 1425 ottobre 31 Prohibition to demand payment, cancellation of debt and restitution of pawns. quartiere di Santa Maria Novella
o0204011.028vc 1425 ottobre 31 Registration of payments received on account of a debt of the Commune of Cerreto. Comune di Cerreto
o0204011.028vd 1425 ottobre 31 Restitution of pawn and exemption from demand of payment for dotal properties. quartiere di Santa Maria Novella
o0204011.073vc 1425 ottobre 31 Term of payment for debt for forced loans. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0202001.012vf 1425 novembre 3 Term of payment to the baptismal parish of Santa Maria Impruneta. piviere di Santa Maria Impruneta
o0204011.073vd 1425 novembre 3 Term of payment for debt for pardons to the baptismal parish of Santa Maria Impruneta. piviere di Santa Maria Impruneta
o0202001.013d 1425 novembre 5 Obligation of payment for property gabelle under penalty demand of payment. quartiere di San Giovanni
o0204011.028vh 1425 novembre 5 Order to possessors of properties of debtor to pay part of his debt. quartiere di San Giovanni
o0202001.013f 1425 novembre 7 Term of payment to the Commune of San Gimignano. Comune di San Gimignano
o0202001.013f 1425 novembre 7 Term of payment to the Commune of San Gimignano. oratorio di San Galgano
o0202001.013g 1425 novembre 7 Prohibition to master mason to work at the castle of Lastra. Comune di Firenze
o0202001.013h 1425 novembre 7 Election of a lawyer for a lawsuit in course over a piece of land located in the Commune of Cesano. Comune di Cesano
o0202001.013h 1425 novembre 7 Election of a lawyer for a lawsuit in course over a piece of land located in the Commune of Cesano. Vicariato di Vicopisano
o0204011.028vl 1425 novembre 7 Election of lawyer for question arisen for reasons of inheritance. Comune di Cesano
o0204011.028vl 1425 novembre 7 Election of lawyer for question arisen for reasons of inheritance. Vicariato di Vicopisano
o0204011.073vg 1425 novembre 7 Term of payment to the Commune of San Gimignano. Comune di San Gimignano
o0204011.073vg 1425 novembre 7 Term of payment to the Commune of San Gimignano. oratorio di San Galgano
o0202001.013vd 1425 novembre 18 Credit of sums paid by the Commune of San Miniato. Comune di San Miniato fiorentino
o0202001.013ve 1425 novembre 18 Term of payment for a property gabelle. pieve di San Giusto in Salcio
o0202001.013vf 1425 novembre 18 Prohibition to demand payment of debtor. pieve di San Giusto in Salcio
o0202001.013vf 1425 novembre 18 Prohibition to demand payment of debtor. quartiere di Santo Spirito
o0202001.013vg 1425 novembre 18 Term of payment given to a debtor. (quartiere di) Santo Spirito
o0202001.013vn 1425 novembre 18 Term of payment to the Commune of Poggibonsi. Comune di Poggibonsi
o0204011.029a 1425 novembre 18 Registration as income of deposit of the Commune of San Miniato. Comune di San Miniato
o0204011.029b 1425 novembre 18 Cancellation of debt to the rector of San Giusto in Salcio. pieve di San Giusto in Salcio
o0204011.029b 1425 novembre 18 Cancellation of debt to the rector of San Giusto in Salcio. quartiere di Santo Spirito
o0204011.074a 1425 novembre 18 Term of payment to the rector of San Giusto in Salcio. pieve di San Giusto in Salcio
o0204011.074b 1425 novembre 18 Term of payment for debt. (quartiere) di Santo Spirito
o0204011.074c 1425 novembre 18 Term of payment to the Commune of Poggibonsi. Comune di Poggibonsi
o0204011.030f 1425 novembre 20 Review of the documentation concerning the debt of the Commune of San Gimignano. Comune di San Gimignano
o0202001.015b 1425 novembre 21 Prohibition to coerce the Commune of San Gimignano to pay. Comune di San Gimignano
o0204011.030a 1425 novembre 21 Revocation of promise of payment made by the Commune of San Gimignano concerning the properties of the oratory of San Galgano. Comune di San Gimignano
o0204011.030a 1425 novembre 21 Revocation of promise of payment made by the Commune of San Gimignano concerning the properties of the oratory of San Galgano. oratorio di San Galgano
o0202001.015vc 1425 novembre 23 Letter to the Podestà of Vicopisano instructing him to demand payment of debtor for a piece of land located at Cesano, which is the object of litigation with the Opera. Comune di Cesano
o0202001.015vc 1425 novembre 23 Letter to the Podestà of Vicopisano instructing him to demand payment of debtor for a piece of land located at Cesano, which is the object of litigation with the Opera. Vicariato di Vicopisano
o0202001.015vc 1425 novembre 23 Letter to the Podestà of Vicopisano instructing him to demand payment of debtor for a piece of land located at Cesano, which is the object of litigation with the Opera. Comune di Vicopisano
o0202001.015vc 1425 novembre 23 Letter to the Podestà of Vicopisano instructing him to demand payment of debtor for a piece of land located at Cesano, which is the object of litigation with the Opera. corte del Podestà di Vico
o0202001.015vc 1425 novembre 23 Letter to the Podestà of Vicopisano instructing him to demand payment of debtor for a piece of land located at Cesano, which is the object of litigation with the Opera. Comune di Firenze
o0202001.017a 1425 novembre 23 Term of payment for debt for forced loans. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0204009.113vd 1425 novembre 23 Payment for reimbursement of pardons paid twice. Comune di Cerreto Guidi
o0204011.074d 1425 novembre 23 Term of payment given to a debtor. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0204011.030vf 1425 dicembre 10 Prohibition to demand payment of guarantor for debt. pieve di Santo Stefano
o0202001.018d 1425 dicembre 12 Terms of payment to debtors. corte del Podestà di Firenze
o0204011.030vh 1425 dicembre 12 Summons of debtor arrested by the Podestà. (corte) del Podestà di Firenze
o0202001.018vb 1425 dicembre 13 Term of payment. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0202001.018vd 1425 dicembre 13 Authority to the administrator of Lastra to build a road around to the walls of the castle. Comune di Malmantile
o0204011.030vi 1425 dicembre 13 Letter to the Captain of Volterra instructing him to compel a kilnman to make payment. badia di Settimo
o0204011.074g 1425 dicembre 13 Term of payment given to a debtor. (quartiere) di Santa Maria Novella
o0204011.074vc 1425 dicembre 23 Term of payment to the Commune of Gangalandi. Comune di Gangalandi
o0202001.019e 1425 dicembre 24 Term to the Commune of Gangalandi. Comune di Gangalandi
o0202001.020a 1425/6 gennaio 10 Term of payment to the Commune of Prato. Comune di Prato
o0202001.020b 1425/6 gennaio 10 Release of kilnmen from the payment of sum advanced for supply of broad bricks and new commitment of the sons of one of them. piviere di Settimo
o0202001.020b 1425/6 gennaio 10 Release of kilnmen from the payment of sum advanced for supply of broad bricks and new commitment of the sons of one of them. ufficio dei Dieci di Pisa
o0202001.020c 1425/6 gennaio 10 Letter to the Commune and to the Podestà of Montemurlo for debt of the baptismal parish of said place. Comune di Montemurlo
o0202001.020c 1425/6 gennaio 10 Letter to the Commune and to the Podestà of Montemurlo for debt of the baptismal parish of said place. pieve di Montemurlo
o0204011.031f 1425/6 gennaio 10 Release of kilnman from commitment to convey broad bricks and confirmation of his partner's liability. badia di Settimo
o0204011.074ve 1425/6 gennaio 10 Letter to the Podestà of Montemurlo for debt of the baptismal parish of said place. Comune di Montemurlo
o0204011.074ve 1425/6 gennaio 10 Letter to the Podestà of Montemurlo for debt of the baptismal parish of said place. pieve di Montemurlo
o0202001.020e 1425/6 gennaio 18 Term of payment to the communes of Signa and of Pontorme for debt for pardons. Comune di Signa
o0202001.020e 1425/6 gennaio 18 Term of payment to the communes of Signa and of Pontorme for debt for pardons. Comune di Pontorme
o0204011.074vf 1425/6 gennaio 18 Term of payment to the Commune of Montelupo for debt for pardons. Comune di Montelupo
o0204011.074vg 1425/6 gennaio 18 Term of payment for debt for pardons to the Commune of Signa. Comune di Signa
o0202001.020va 1425/6 gennaio 24 Term of payment to the communes of Empoli and Poggibonsi. Comune di Empoli
o0202001.020va 1425/6 gennaio 24 Term of payment to the communes of Empoli and Poggibonsi. Comune di Poggibonsi
o0204011.075a 1425/6 gennaio 24 Term of payment to the Commune of Empoli. Comune di Empoli
o0204011.075c 1425/6 gennaio 24 Term of payment to the Commune of Poggibonsi. Comune di Poggibonsi
o0202001.020vc 1425/6 gennaio 25 Term of payment to the Commune of Figline. Comune di Figline
o0204011.075f 1425/6 gennaio 25 Term of payment to the Commune of Figline. Comune di Figline
o0204011.031vd 1425/6 gennaio 28 Release of arrested person. Comune di Barberino
o0204011.031vd 1425/6 gennaio 28 Release of arrested person. chiesa di San Salvestro di Barberino
o0204011.031vd 1425/6 gennaio 28 Release of arrested person. chiesa di San Salvestro di Barberino
o0204011.075h 1425/6 gennaio 28 Term of payment to the guarantor of the Commune of Romena. Comune di Romena
o0202001.021e 1425/6 gennaio 29 Term of payment to the guarantor of the Commune of Romena. Comune di Romena
o0202001.021g 1425/6 gennaio 29 Release of priest arrested for debt. Comune di Barberino
o0202001.021g 1425/6 gennaio 29 Release of priest arrested for debt. chiesa di San Salvestro
o0202001.022e 1425/6 febbraio 15 Letter to the administrator of Pisa instructing him to nominate a notary for the collection of the tax on testaments. Comune di Pisa
o0202001.024b 1425/6 marzo 12 Term of payment given to debtors. quartiere di Santa Croce
o0202001.024va 1425/6 marzo 12 Term of payment given to debtors. quartiere di Santo Spirito
o0204011.075vc 1425/6 marzo 12 Term of payment given to a debtor. quartiere di Santa Croce
o0204011.075ve 1425/6 marzo 12 Term of payment given to a debtor. quartiere di Santo Spirito
o0202001.025va 1425/6 marzo 21 Term of payment for debt to the Commune of Prato. Comune di Prato
o0202001.025vd 1425/6 marzo 21 Term of payment for debt. quartiere di San Giovanni
o0202001.025vf 1425/6 marzo 21 Term of payment given to a debtor. quartiere di San Giovanni
o0202001.025vh 1425/6 marzo 21 Term of payment given to debtors. quartiere di San Giovanni
o0202001.025vi 1425/6 marzo 21 Unfinished act concerning a debtor. quartiere di Santa Maria Novella
o0202001.026a 1425/6 marzo 21 Approval of term and guaranty for the debt of Commune of Incisa. Comune di Incisa
o0202001.026c 1425/6 marzo 21 Authority to warden for cancellation of a debt after obtaining a greater sum from the pawns sold. quartiere di Santo Spirito
o0204011.033ve 1425/6 marzo 21 Approval of term of payment to the Commune of Incisa. Comune di Incisa
o0204011.033vg 1425/6 marzo 21 Authority to warden for audit of account entry of debtor. quartiere di Santo Spirito
o0204011.075vg 1425/6 marzo 21 Term of payment to the Commune of Empoli. Comune di Empoli
o0204011.076b 1425/6 marzo 21 Term of payment for debt. quartiere di San Giovanni
o0204011.076c 1425/6 marzo 21 Term of payment for debt. quartiere di San Giovanni
o0204011.076f 1425/6 marzo 21 Unfinished act concerning debtor of the Opera. quartiere di Santa Maria Novella
o0204011.034d 1425/6 marzo 23 Letter to the master of glass windows for two oculi that he has to make for the Opera, under penalty of demand of payment of the persons standing surety for him. ordine di San Domenico
o0202001.027h 1426 aprile 17 Letters to the rectors and officials of the countryside about norms for demand of payment of the debtors served with notice. Podesteria di Dicomano
o0202001.027vd 1426 aprile 21 Authority to wardens for the work at Lastra and Malmantile; sentence and fine of defaulting master; acquittal and new contract for the work. Comune di Gangalandi
o0202001.027vd 1426 aprile 21 Authority to wardens for the work at Lastra and Malmantile; sentence and fine of defaulting master; acquittal and new contract for the work. Popolo e Comune di Firenze
o0202001.027vd 1426 aprile 21 Authority to wardens for the work at Lastra and Malmantile; sentence and fine of defaulting master; acquittal and new contract for the work. Camera del Comune di Firenze
o0202001.027vd 1426 aprile 21 Authority to wardens for the work at Lastra and Malmantile; sentence and fine of defaulting master; acquittal and new contract for the work. Comune di Firenze
o0202001.028va 1426 aprile 23 Release of debtor and redraft of his emancipated sons. Comune di San Giovanni Valdarno di sopra
o0202001.028va 1426 aprile 23 Release of debtor and redraft of his emancipated sons. Comune di San Giovanni Valdarno di sopra
o0202001.028vd 1426 aprile 29 Term of payment given to debtors. piviere di Fiesole
o0202001.029e 1426 aprile 29 Sentence condemning accountant for missing report on a dispute between the Opera and the suppliers of white marble, with final term for its presentation to the consuls or the wardens. Comune di Firenze
o0202001.029e 1426 aprile 29 Sentence condemning accountant for missing report on a dispute between the Opera and the suppliers of white marble, with final term for its presentation to the consuls or the wardens. Camera del Comune di Firenze
o0202001.030vd 1426 aprile 29 Term of payment to the baptismal parish of Cintoia. piviere di Cintoia
o0204011.076vg 1426 aprile 29 Term of payment to the rector of Cintoia. pieve di Cintoia
o0202001.031d 1426 aprile 30 Cancellation of sentence. Camera del Comune di Firenze
o0202001.031d 1426 aprile 30 Cancellation of sentence. Camera degli atti del Comune di Firenze
o0202001.031vc 1426 maggio 10 Prohibition to demand payment of the parish of San Giovanni of Senni for unregistered properties. popolo di San Giovanni di Senni
o0202001.031vc 1426 maggio 10 Prohibition to demand payment of the parish of San Giovanni of Senni for unregistered properties. popolo di San Giovanni di Senni
o0202001.031ve 1426 maggio 10 Term of payment to the church of San Bartolomeo a Ripalta. chiesa di San Bartolomeo a Ripalta
o0204011.077a 1426 maggio 10 Term of payment to the church of San Bartolomeo a Ripalta. chiesa di San Bartolomeo di Ripalta
o0204011.077a 1426 maggio 10 Term of payment to the church of San Bartolomeo a Ripalta. chiesa di San Bartolomeo di Ripalta
o0202001.032va 1426 maggio 15 Letter to the Podestà of Prato instructing him to absolve the Commune of Prato if he receives notice that it has obeyed the mandates of the wardens, otherwise he is to compel two arrested persons in his court to appear before the wardens. Comune di Prato
o0202001.032va 1426 maggio 15 Letter to the Podestà of Prato instructing him to absolve the Commune of Prato if he receives notice that it has obeyed the mandates of the wardens, otherwise he is to compel two arrested persons in his court to appear before the wardens. corte del Podestà di Prato
o0204012.014a 1426 maggio 15 Advance on payment to kilnman for a load of large broad bricks. badia di Settimo
o0202001.033b 1426 maggio 17 Letters to the captains of Pisa and Livorno about the white marble to be conveyed. Comune di Firenze
o0202001.033c 1426 maggio 17 Letter to the Podestà of Dicomano instructing him to make provision for repairing the road ruined by the war which is useful for conveying lumber to the Opera. Comune di Castagno
o0202001.033d 1426 maggio 17 Letter to the Commune of Corniolo ordering it to substitute or reimburse the cut and rough-hewn lumber that had been carried out of the forest of the Opera. Comune di Corniolo
o0204012.014d 1426 maggio 23 Payment to the Commune of Castagno for the purchase of lumber. Comune di Castagno
o0202001.033va 1426 maggio 31 Revocation of fine to workers for just impediment that cropped up at the conclusion of the work on the castle of Lastra. Comune di Firenze
o0202001.033va 1426 maggio 31 Revocation of fine to workers for just impediment that cropped up at the conclusion of the work on the castle of Lastra. Comune di Gangalandi
o0202001.033va 1426 maggio 31 Revocation of fine to workers for just impediment that cropped up at the conclusion of the work on the castle of Lastra. Camera degli atti del Comune di Firenze
o0202001.034va 1426 giugno 7 Declaration in favor of the treasurer of the salt gabelle for having paid the amount due to the Opera in accordance with the ordinances of the Commune. Popolo e Comune di Firenze
top of page Return Help Contact home
© 2015 Opera di Santa Maria del Fiore