space Studies Sources Dates Indices Topics1 Topics2 Reference Texts


SUMMARIES


WordsinSUMMARIES


LINKS


REFERENCES


WordsinREFERENCES


A-E

F-K


L-O


P-S


T-Z


0-9


OTHER


BIBLIOGRAPHY

A1-150  A151-300  A301-450  A451-600  601-750 A751-900  A901-1022 


Previous
di
Next
 

sorted
Document

sort
Date

sort
Summary

sort
Context of query
o0202001.030vb 1426 aprile 29 Election of unskilled worker for Trassinaia with salary set. Libro dei manovali di Trassinaia
o0202001.038va 1426 agosto 8 Order to the notary and treasurer to register as income a sum deposited for pardon of sentence of the Commune of Florence, with discount of a florin already paid. Libro dell'entrata di Giovanni d'Onofrio Bischeri, c. 2
o0202001.039vf 1426 agosto 27 Term of payment for debt for forced loans. Registro delle prestanze di Santo Spirito, c. 49
o0202001.039vg 1426 agosto 27 Term of payment to guarantor. Registro di Santo Spirito, c. 13
o0202001.047a 1426 dicembre 11 Term of payment to vintner. Quartiere di San Giovanni, c. 74
o0202001.048vb 1426 dicembre 30 Attribution to the sacristy of all the oblations made to the church, to be spent according to the indications of the sacristy officials. Bolla di Giovanni XXIII
o0202001.050d 1426/7 gennaio 28 Term of payment to guarantor for debt for forced loans. Registro di Santo Spirito
o0202001.051d 1426/7 febbraio 4 Term of payment to the Commune of Prato for debt for pardons. Registro delle grazie di otto anni e due mesi
o0202001.053d 1426/7 febbraio 28 Concession of right of recourse to guarantor for debt for forced loans. Registro delle prestanze di Santo Spirito, c. 16
o0202001.053vc 1426/7 marzo 6 Term of payment and revocation of demand of payment for debt. Registro di Santa Maria Novella, c. 51
o0202001.054b 1426/7 marzo 15 Term of payment for debt for forced loans. Registro delle prestanze del quartiere di Santo Spirito, c. 60
o0202001.055b 1427 aprile 2 Term of payment for debt for forced loans. Registro delle prestanze di Santo Spirito, c. 49
o0202001.059vf 1427 maggio 7 Account of the treasurer of the forced loans: unfinished act. Quaderni dei camarlinghi del Comune di Firenze, c. 44
o0202001.068f 1427 settembre 23 Release of imprisoned person with order slip issued by the notary of the Opera. Bollettino di rilascio
o0202001.075va 1427/8 gennaio 8 Oath of three wardens. Statuti del Comune di Firenze
o0202001.075va 1427/8 gennaio 8 Oath of three wardens. Ordinamenti del Comune di Firenze
o0202001.077b 1427/8 gennaio 22 Cancellation of debt for new gabelles and restitution of deposit. Estimo di San Giovanni di Senni
o0202001.077b 1427/8 gennaio 22 Cancellation of debt for new gabelles and restitution of deposit. Estimo di San Giovanni di Senni
o0202001.078vg 1427/8 febbraio 24 Acquittal in favor of San Gimignano in the dispute over testamentary legacies. Ordinamenti del Popolo e Comune di Firenze
o0202001.082i 1428 aprile 30 Term of payment to heirs for the payment of legacies. Registro del quartiere di Santa Croce, c. 25
o0202001.082i 1428 aprile 30 Term of payment to heirs for the payment of legacies. Registro del quartiere di Santa Croce, c. 70
o0202001.082va 1428 maggio 5 Notification to the Alessandri heirs of the forthcoming restitution of the shed and garden held in loan against security, in accordance with the ten-year agreements signed with their father. Libro di ricordanze e deliberazioni del provveditore dell'Opera, c. 82
o0202001.083vc 1428 maggio 12 Term of payment for debt for pardons and for the wine and butchering gabelles to the Commune of San Miniato. Registro delle grazie di otto anni e due mesi
o0202001.091b 1428 agosto 31 Term of payment to the parish and to the baptismal parish of Remole di sopra. Registro delle grazie di otto anni e due mesi, c. 60
o0202001.092m 1428 ottobre 1 Exemption allowed to heirs for gabelle on contracts. Registro terzo di Santa Maria Novella, c. 42
o0202001.097vg 1428 dicembre 20 Term of payment for debt for forced loans and possibility of release of (debtor). Bollettino di rilascio
o0202001.100vh 1428/9 febbraio 18 Term of payment given to debtors. Registro delle prestanze di Santa Maria Novella, c. 13
o0202001.101b 1428/9 febbraio 14 Term of payment to debtor for wine gabelle. Bollettino di rilascio
o0202001.102va 1428/9 febbraio 23 Authorization to cancel debtor and term of payment to newly registered replacement. Registro del quartiere di Santa Maria Novella
o0202001.103b 1428/9 marzo 12 Term of payment given to a debtor. Registro del quartiere di Santa Croce
o0202001.107vf 1429 giugno 3 Concession of right of recourse to stonecutter. Entrata di Domenico Giugni
o0202001.112f 1429 settembre 12 Oath of wardens. Statuti del Comune di Firenze
o0202001.114vb 1429 ottobre 15 Suspension of payment and new term for debt for forced loans. Quaderno di cassa di Niccolò Barbadori
o0202001.114vb 1429 ottobre 15 Suspension of payment and new term for debt for forced loans. Quaderno di cassa di Niccolò Barbadori
o0202001.114vc 1429 ottobre 15 Salary of masters for the winter. Libro delle giornate di Filippozzo di Giovenco Bastari
o0202001.114vc 1429 ottobre 15 Salary of masters for the winter. Libro delle giornate di Filippozzo di Giovenco Bastari
o0202001.115vd 1429 ottobre 26 Cancellation of debit entry registered twice. Registro delle prestanze di Santa Croce, c. 38
o0202001.115vd 1429 ottobre 26 Cancellation of debit entry registered twice. Registro di Santa Croce, c. 38
o0202001.118e 1429 dicembre 2 Term of payment for debt for forced loans. Registro delle prestanze del quartiere di Santa Maria Novella, c. 18
o0202001.118vc 1429 dicembre 12 Precept for summons and term of payment to debt collectors. Quaderno del camarligato di Bartolo di Schiatta Ridolfi
o0202001.118vc 1429 dicembre 12 Precept for summons and term of payment to debt collectors. Quaderno del camarligato di Bartolo di Schiatta Ridolfi
o0202001.119d 1429 dicembre 19 Demand of payment of (debt collector) debtor. Quaderno di cassa di Bartolo di Schiatta Ridolfi
o0202001.119d 1429 dicembre 19 Demand of payment of (debt collector) debtor. Quaderno di cassa di Bartolo di Schiatta Ridolfi
o0202001.119d 1429 dicembre 19 Demand of payment of (debt collector) debtor. Quaderno di cassa di Bartolo di Schiatta Ridolfi
o0202001.124l 1429/30 marzo 22 Annulment of testamentary debt and prohibition to demand payment because of renunciation of inheritance. Registro terzo di Santa Croce, c. 156
o0202001.124m 1429/30 marzo 22 Term of payment for debt for forced loans. Registro delle prestanze di Santa Maria Novella, c. 28
o0202001.124m 1429/30 marzo 22 Term of payment for debt for forced loans. Registro delle prestanze di Santa Maria Novella, c. 54
o0202001.127e 1430 maggio 11 Term of payment for debt for forced loans and livestock gabelle. Registro delle prestanze di San Giovanni, c. 38
o0202001.127va 1430 maggio 19 Term of payment for debt for forced loans with restitution of pawn. Registro delle prestanze di Santa Maria Novella, c. 17
o0202001.127vb 1430 maggio 19 Term of payment for debt for forced loans and property gabelle with release of arrested person. Registro delle prestanze di San Giovanni, c. 35
o0202001.127vb 1430 maggio 19 Term of payment for debt for forced loans and property gabelle with release of arrested person. Registro della gabella dei beni di San Giovanni, c. 93
o0202001.127vd 1430 maggio 19 Term of payment for debt for forced loans with release of arrested person. Registro delle prestanze di San Giovanni, c. 19
o0202001.132ve 1430 ottobre 5 Term of payment to the Commune of Firenzuola and to the Florentine Alps. Quaderno delle rimesse del passo di Cavrenno, c. 7
o0202001.132vi 1430 ottobre 5 Conditions of payment to a debtor and revocation of demand of payment. Quaderno della gabella delle porte del Comune di Firenze
o0202001.133vd 1430 novembre 29 Term of payment to a butcher. Quaderno dei rinterzi di macello, c. 21
o0202001.134e 1430 dicembre 7 Term of payment to a debtor. Registro delle prestanze di Santa Maria Novella, c. 13
o0202001.136b 1430/1 gennaio 22 Term of payment to a debtor. Registro delle prestanze del quartiere di San Giovanni, c. 39
o0202001.136vb 1430/1 gennaio 26 Order to build the altar of Saint Zenobius and commission for a model of it. Riformagione del Comune per sepoltura di San Zanobi
o0202001.138ve 1430/1 marzo 8 Revocation of demand of payment for testament. Registro terzo di San Giovanni, c. 4
o0202001.144vh 1431 giugno 28 Term of payment given to debtors. Registro delle prestanze di San Giovanni, c. 18
o0202001.145va 1431 luglio 11 Term of payment for the new gabelles given to debtors. Registro di Santo Spirito, c. 41
o0202001.145va 1431 luglio 11 Term of payment for the new gabelles given to debtors. Registro di Santo Spirito, c. 81
o0202001.145vf 1431 luglio 13 Revocation of demand of payment for forced loans pertaining to a farm on account of error of identity of person. Registro delle prestanze di San Giovanni
o0202001.149a 1431 settembre 27 Declaration of the names of the debtors and of the sums owed regarding a big credit of the Opera for the pardons of forced loans of the Alberti. Libro di ricordanze B di Benedetto di Bernardo di messer Benedetto Alberti e compagni fondacai, c. 3
o0202001.149a 1431 settembre 27 Declaration of the names of the debtors and of the sums owed regarding a big credit of the Opera for the pardons of forced loans of the Alberti. Libro di ricordanze B di Benedetto di Bernardo di messer Benedetto Alberti e compagni fondacai, c. 3
o0202001.149a 1431 settembre 27 Declaration of the names of the debtors and of the sums owed regarding a big credit of the Opera for the pardons of forced loans of the Alberti. Libro di ricordanze B di Benedetto di Bernardo di messer Benedetto Alberti e compagni fondacai, c. 3
o0202001.149a 1431 settembre 27 Declaration of the names of the debtors and of the sums owed regarding a big credit of the Opera for the pardons of forced loans of the Alberti. Libro di ricordanze B di Benedetto di Bernardo di messer Benedetto Alberti e compagni fondacai, c. 3
o0202001.153f 1431/2 gennaio 18 Ratification of contracts made for lumber. Nota di allogagioni data al provveditore
o0202001.160vb 1432 maggio 14 Revocation of a demand of payment for reasons of dowry. Registro dei beni di Santa Croce, c. 1
o0202001.161i 1432 maggio 28 Correction of an entry for allocation of funds occurring twice. Quaderno di Tommaso Barbadori
o0202001.163vf 1432 luglio 9 Release of arrested person because not heir of a testamentary debt. Registro quinto di Santo Spirito, c. 1
o0202001.164h 1432 aprile 14 Salary set for masters. Scritto dei salari dei maestri di mano dello scrivano delle giornate.
o0202001.165f 1432 luglio 15 Term of payment for forced loans. Registro delle prestanze di Santa Maria Novella, c. 8
o0202001.165va 1432 luglio 15 Tare for supply of broad bricks fired badly. Quaderno di Filippo
o0202001.167vc 1432 agosto 14 Notification to the treasurers (of the Commune) to pay money due in accordance with the statutes. Provvisione su termini di pagamento dai camarlinghi del Comune
o0202001.187vi 1432 ottobre 1 Term of payment with restitution of pawn. Registro delle prestanze di Santa Maria Novella, c. 28
o0202001.188f 1432 ottobre 3 Term of payment for new gabelles. Registro delle prestanze di Santo Spirito
o0202001.191vc 1432 dicembre 3 Restitution of pawn to the holder of a house obtained through the officials of the Commune from a rebel and debtor of the Opera. Riformagione di novembre 1400 su vendita beni dei ribelli
o0202001.192vd 1432 dicembre 9 Order to have the new headquarters for the officials of the Opera and covered areas for the stonecutters and lumber made in the garden and shed of the Tedaldi. Riformagione su acquisto di case
o0202001.203c 1433 luglio 13 Term of payment. Registro delle prestanze di Santo Spirito, c. 28
o0202001.210a 1433/4 febbraio 3 Term for the forced sale to the Opera of a shed and of a garden intended for the use of Opera personnel. Provvisione di dicembre 1339 per balia all'Arte della Lana e Opera su acquisti
o0202001.212e 1433/4 marzo 24 Revocation of demand of payment against the hospital of Santa Maria della Scala, heir of a debtor of the Opera. Quartiere di Santo Spirito, c. 28
o0202001.216va 1434 maggio 14 Affirmation of debt for pardons of taxes, on the basis of legal counsel, and mode of payment. Provvisione del febbraio 1431/2 a favore di Bernardo Guasconi
o0202001.227vg 1434/5 febbraio 22 Letter to the supervisors of Pisa about the rebels' properties to be confiscated up to the sum of 1500 florins. Catasto di Pisa
o0202001.227vg 1434/5 febbraio 22 Letter to the supervisors of Pisa about the rebels' properties to be confiscated up to the sum of 1500 florins. Provvisione dei Signori per consegna dei beni dei ribelli di Pisa
o0202001.231va 1435 aprile 26 Acquittal of a treasurer of the forced loans from the payment of 6 denari per lira. Consiglio dei Signori e collegi a favore di pupilli e vedove
o0202001.239vh 1435 agosto 19 Authority to the wardens to attend the ordination of 25 choir boys and their master in accordance with the will of Pope Eugenius IV. Bolle di Eugenio IV
o0202001.250a 1435/6 marzo 8 Order to the notary of the Opera to have the arrested persons for the Commune of Firenzuola released. Bollettino del notaio dell'Opera per liberazione di catturati
o0202001.253i 1436 maggio 4 Authorization to give thirty fir logs to the friars of San Domenico of Fiesole. Provvisione dei consigli del Popolo e del Comune di Firenze a favore di S. Domenico
o0202001.253i 1436 maggio 4 Authorization to give thirty fir logs to the friars of San Domenico of Fiesole. Provvisione dei consigli del Popolo e del Comune di Firenze a favore di S. Domenico
o0202001.255b 1436 giugno 19 Acquittal of notified debtors and letter to the vicar of val d'Elsa for release of imprisoned laborers. Registro delle prestanze di Santo Spirito
o0202001.258b 1426 novembre 8 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Debitori e creditori del Comune di Gangalandi, manifatture C, c. 4
o0202001.258b 1426 novembre 8 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Debitori e creditori del Comune di Gangalandi C, c. 9
o0202001.258b 1426 novembre 8 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Debitori e creditori di Gangalandi C, c. 12
o0202001.258b 1426 novembre 8 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Debitori e creditori di Gangalandi C, cc.19-20
o0202001.258b 1426 novembre 8 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Debitori e creditori di Gangalandi C, c. 22
o0202001.258b 1426 novembre 8 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Debitori e creditori di Gangalandi C, c. 26
o0202001.258b 1426 novembre 8 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Debitori e creditori di Gangalandi C, cc. 27-28
o0202001.258b 1426 novembre 8 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Specchio del Comune di Gangalandi, c. 315
o0202001.258b 1426 novembre 8 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Specchio del Comune di Gangalandi, c. 321
o0202001.258b 1426 novembre 8 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Specchio del Comune di Gangalandi, c. 370
o0202001.258b 1426 novembre 8 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Uscita di Carlo, cc. 50-70
o0202001.258c 1426 novembre 14 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Debitori e creditori del Comune di Gangalandi, manifatture C, c. 13
o0202001.258c 1426 novembre 14 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Debitori e creditori del Comune di Gangalandi, manifatture, cc. 23-25
o0202001.258c 1426 novembre 14 Audit of accounts of master masons for work at the castle of Lastra. Debitori e creditori del Comune di Gangalandi, manifatture, cc. 29-30
o0204004.005vh 1432 luglio 15 Payment for the purchase of broad bricks. Libro di Filippozzo
o0204008.001a 1417 Incipit of the notebook of allocations of funds of the wardens. Quaderno di stanziamenti RR
o0204008.004vf 1417 maggio 21 Reimbursement of a double payment for testamentary rights. Registro secondo di Santa Croce, c. 13
o0204008.030va 1418 ottobre 24 Payment for petty expenses. Uscita di Filippo Guasconi, c. 39
o0204008.031a 1418 ottobre 23 Payment for expenditures for the celebrations of Saint Reparata and Saint Dionysius. Uscita del camarlingo Filippo di messer Biagio, c. 44
o0204008.036a 1418 dicembre 23 Payment for petty expenses. Uscita di Filippo di messer Biagio, c. 43
o0204008.036a 1418 dicembre 23 Payment for petty expenses. Uscita di Filippo di messer Biagio, c. 43
o0204008.041a 1419 aprile 22 Payment for various expenditures. Uscita di Filippo Giugni, c. 37
o0204008.045a 1418 aprile 14 Payment to a stationer for various supplies. Condanna di ser Michele di ser Bonaccorso
o0204008.045a 1418 aprile 14 Payment to a stationer for various supplies. Condanna di ser Michele di ser Bonaccorso
o0204008.045a 1418 aprile 14 Payment to a stationer for various supplies. Condanna di ser Niccolò Tinucci
o0204008.048vb 1419 agosto 11 Payment for counsel requested of various lawyers and to a notary for copying an act. Uscita di Migliorino Guidotti, c. 37
o0204008.055vb 1419 ottobre 7 Revocation of allocation of funds for alterations in a rented house. Quaderno di cassa
o0204008.056b 1419 ottobre 7 Payment for petty expenses. Uscita di Migliorino, c. 38
o0204008.059va 1419 dicembre 15 Payment for petty expenses. Uscita di Migliorino Guidotti, c. 33
o0204008.084vb 1420 giugno 28 Restitution of sum erroneously written to debt. Quaderno di cassa del camarlingo Migliorino Guidotti, c. 24
o0204008.088a 1420 settembre 4 Payment for various expenditures. Uscita di Andrea Del Palagio, c. 62
o0204008.097va 1420 dicembre 20 Payment for rights of collection of pawns and restitution of possible surplus gained from the sale. Quaderno di cassa di Andrea Del Palagio
o0204008.097va 1420 dicembre 20 Payment for rights of collection of pawns and restitution of possible surplus gained from the sale. Quaderno di cassa di Andrea Del Palagio
o0204008.103a 1420/1 gennaio 7 Payment for petty expenses. Quaderno di Simone da Filicaia
o0204008.105a 1420/1 marzo 19 Payment for petty expenses. Uscita di Bartolo di Schiatta, c. 53
o0204008.105a 1420/1 marzo 19 Payment for petty expenses. Uscita di Bartolo di Schiatta, c. 53
o0204008.109vf 1421 maggio 29 Payment for copying the debtors of the Opera from the book of forced loans. Estratto di debitori di grazie ricevute per prestanze
o0204008.109vf 1421 maggio 29 Payment for copying the debtors of the Opera from the book of forced loans. Estratto di debitori di grazie ricevute per prestanze
o0204008.111a 1421 giugno 5 Payment for petty expenses. Uscita di Giovanni di messer Forese camarlingo, c. 50
o0204008.111a 1421 giugno 5 Payment for petty expenses. Uscita di Giovanni di messer Forese camarlingo, c. 50
o0204008.111b 1421 giugno 5 Payment of legal expenses for the lawsuit of the recourse of the sons of messer Bartolomeo Panciatichi. Uscita del camarlingo Giovanni di messer Forese, c. 50
o0204008.112a 1420 dicembre 30 Salary allowance of the treasurer of the Pope's residence. Quadernuccio di ricordanze RR, c. 29
o0204009.007va 1421 novembre 5 Payment for reimbursement of travel expenditures to have lumber transported. Scritte di Jacopo di Sandro infilzate
o0204009.007va 1421 novembre 5 Payment for reimbursement of travel expenditures to have lumber transported. Scritte di Jacopo di Sandro infilzate
o0204009.010ve 1420 agosto 5 Payment to stationer. Quaderno di termini e malleverie
o0204009.010ve 1420 agosto 5 Payment to stationer. Quadernuccio del camarlingo Bartolo di Schiatta
o0204009.011a 1421 dicembre 5 Payment to stationer. Libro ZZ per debitori di grazie
o0204009.011a 1421 dicembre 5 Payment to stationer. Libro di ser Niccolò Attavanti
o0204009.011a 1421 dicembre 5 Payment to stationer. Quaderno di cassa del camarlingo Giovanni di messer Forese
o0204009.011a 1421 dicembre 5 Payment to stationer. Quaderno di cassa del camarlingo Giovanni di messer Forese
o0204009.011a 1421 dicembre 5 Payment to stationer. Libro di Filippozzo Bastari
o0204009.011a 1421 dicembre 5 Payment to stationer. Quaderno di deliberazioni di ser Dino di Cola
o0204009.011a 1421 dicembre 5 Payment to stationer. Quaderno di deliberazioni di ser Dino di Cola
o0204009.011a 1421 dicembre 5 Payment to stationer. Quaderno di deliberazioni di ser Dino di Cola
o0204009.011vf 1421 novembre 21 Payment to messenger for collection of money from the Tower office. Uscita di Giovanni di messer Forese camarlingo, c. 60
o0204009.011vf 1421 novembre 21 Payment to messenger for collection of money from the Tower office. Uscita di Giovanni di messer Forese camarlingo, c. 60
o0204009.012va 1421 ottobre 11 Payment for petty expenses. Quaderno di Simone da Filicaia, c. 5
o0204009.013va 1421 dicembre 23 Payment for petty expenses. Uscita di Giovanni di messer Forese, c. 62
o0204009.013va 1421 dicembre 23 Payment for petty expenses. Uscita di Giovanni di messer Forese, c. 62
top of page Return Help Contact home
© 2015 Opera di Santa Maria del Fiore